Mayor/Alcaldesa 1. Prayer/ Rezo 2. Pledge of Allegiance/Juramento a la Alianza City Clerk:/Secretaria de la Ciudad 3. Roll Call/ Lista de Asistencia
Communications/Communicaciones Approval of Minutes for the meeting of October 22, 2018 Aprobación de los minutos de la reunión del 22 de octubre de 2018
City Manager Update / Gerente de la Ciudad pone al día a la audiencia de los planes de cada departamento
Public Hearing -- 2019 Budget A public hearing will be held on Tuesday, November 13, 2018 to hear comment on the 2019 budget for the City of Newburgh. Una audiencia pública se llevara a cabo el martes, 13 de noviembre de 2018 para escuchar comentarios sobre el presupuesto del 2019 para la Ciudad de Newburgh.
Comments from the public regarding agenda and general matters of City Business/Comentarios del público con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad.
Comments from the City Council
Comments from the Council regarding the agenda/Comentarios del Consejo con respecto a la agenda
City Manager’s Report/ Informe del Gerente de la Ciudad Resolution No. 321 - 2018 Proposal with O'Brien & Gere for Engineering Services at Brown's Pond Resolution authorizing the City Manager to accept a proposal and execute an professional engineering services agreement with O’Brien & Gere Engineers, Inc. for evaluation and rehabilitation investigation of the Brown's Pond spillway at a cost of $47,000.00. (Jason Morris) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a aceptar una propuesta y ejecutar un acuerdo de servicios de ingeniería profesional con “O’Brien & Gere Engineers, Inc.” para evaluación e investigación de rehabilitación del desagüe del Charco de Brown a un costo de $47,000.00 (Jason Morris)
Resolution No. 322 - 2018 Contract Agreement with Inframark, LLC to Operate the WWTP Resolution authorizing the City Manager to execute a Wastewater Treatment Plant Operation and Maintenance Agreement with Inframark, LLC for the operation, maintenance and management of the City Waste Water Treatment Plant. (Jason Morris) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo de mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales con “Inframark, LLC” para la administración, mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de la Ciudad. (Jason Morris)
Resolution No. 323 - 2018 Supplemental Agreement#1 with NYSDOT for the Lake Drive Bridge Replacement Resolution authorizing the City Manager to execute Supplemental Agreement No. 1 with the New York State Department of Transportation to fund in the first instance 100% of the federal-aid and non-federal aid eligible costs for the right-of-way acquisition work for the replacement of the Lake Drive Bridge. (Jason Morris) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar el Acuerdo Suplementario No. 1 con el Departamento de Transportación del Estado de Nueva York para financiar en la primera instancia 100% de los costos elegibles de la ayuda federal y ayuda no federal para la adquisición de trabajo del reemplazo del puente “Lake Drive”. (Jason Morris)
Resolution No. 324 - 2018 Orange County tax exemption agreement -- City of Newburgh water supply property Resolution requesting an exemption from County taxes for the City's reservoir and filter plant properties for the year 2020. (Charles Duffy & Michelle Kelson) Una resolución solicitando una exención de los impuestos del Condado para las propiedades de la planta de depósito y filtro para el año 2020. (Charles Duffy y Michelle Kelson)
Resolution No. 325 - 2018 Surplus bluestone Resolution declaring bluestone slate as surplus and authorizing disposition to the owner of property located at 55 Broad Street. (Michelle Kelson) Una resolución declarando el material “bluestone” como excedente y autorizando su disposición al dueño de la propiedad ubicada en la 55 de la Calle Broad. (Michelle Kelson)
Resolution No. 326 - 2018 Emergency Water Agreement with Town of New Windsor Resolution authorizing the City Manager to execute an inter-municipal emergency water supply agreement with the Town of New Windsor. (Wayne Vradenburgh, Jason Morris & Michelle Kelson) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo inter-municipal de abastecimiento de agua de emergencia con la Ciudad de New Windsor. (Wayne Vradenburgh, Jason Morris y Michelle Kelson)
Resolution No. 327 - 2018 To Accept FY2019 CDBG Funding Resolution adopting the City of Newburgh’s Consolidated Housing and Community Development Strategy and Action Plan for Fiscal Year 2019. (Ali Church) Una resolución adoptando el Plan de Acción y Estrategia de Desarrollo Comunitario y Vivienda Consolidada de la Ciudad de Newburgh para el Año Fiscal 2019. (Ali Church)
Resolution No. 328 - 2018 Purchase of 260 Liberty Street Resolution to authorize the conveyance or real property known as 260 Liberty Street (Section 18, Block 6, Lot 30) at private sale to Jeremy Moore and Heather Moore for the amount of $1,090.00. (Ali Church) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 260 de la Calle Liberty (Sección 18, Bloque 6, Lote 30) en una venta privada a Jeremy Moore y Heather Moore por la cantidad de $1,090.00. (Ali Church)
Resolution No. 329 - 2018 Purchase of 379 First Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 379 First Street (Section 28, Block 1, Lot 16) at private sale to Waldina Almazan for the amount of $65,000.00. (Ali Church) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 379 de la Calle First (Sección 28, Bloque 6, Lote 16) en una venta privada a Waldina Almazan por la cantidad de $65,000.00. (Ali Church)
Resolution No. 330 - 2018 Purchase of 10 Van Ness Street, 12 Van Ness Street and 34 Carter Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 10 Van Ness Street (Section 29, Block 5, Lot 25), 12 Van Ness Street (Section 29, Block 5, Lot 26) and 34 Carter Street (Section 22, Block 2, Lot 26) at private sale to Eulogio and Felderi Santiago for the total amount of $10,000.00. (Ali Church) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 10 de la Calle Van Ness (Sección 29, Bloque 5, Lote 25), 12 de la Calle Van Ness (Sección 29, Bloque 5, Lote 26) y la 34 de la Calle Carter (Sección 22, Bloque 2, Lote 26) en una venta privada a Eulogio y Felderi Santiago por la cantidad total de $10,000.00. (Ali Church)
Resolution 331 - 2018 Purchase of 60 Hasbrouck Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 60 Hasbrouck Street (Section 38, Block 3, Lot 56) at private sale to Michael Lavan for the amount of $50,000.00. (Ali Church) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 60 de la Calle Hasbrouck (Sección 38, Bloque 5, Lote 56) en una venta privada a Michael Lavan por la cantidad de $50,000.00. (Ali Church)
Resolution No. 332 - 2018 Satisfaction of two Mortgages for 173 First Street Resolution authorizing the City Manager to execute satisfactions in connection with mortgages issued to 173 First Street Associates, L.P. for premises located at 173 First Street (Section 30, Block 2, Lot 6) (Ali Church) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad para ejecutar satisfacciones en conexión con las hipotecas emitidas a 173 First Street Associates, L.P. para las instalaciones ubicadas en la 173 de la Calle First (Sección 30, Bloque 2, Lote 6) (Ali Church)
Resolution No. 333 - 2018 Release of Covenants - 92 Fullerton Avenue Resolution authorizing the execution of a release of restrictive covenants and right of re-entry from a deed issued to Leonor Machuca to the premises known as 92 Fullerton Avenue (Section 21, Block 1, Lot 36) (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a Leonor Machuca a las instalaciones conocidas como la 92 de la Avenida Fullerton (Sección 21, Bloque 1, Lote 36) (Michelle Kelson)
Resolution No. 334 - 2018 Release of Covenants -- 167 Ann Street Resolution authorizing the execution of a release of restrictive covenants and right of re-entry from a deed issued to Calixto Cassas to the premises known as 167 Ann Street (Section 36, Block 5, Lot 3) (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a Calixto Cassas a las instalaciones conocidas como la 167 de la Calle Ann (Sección 36, Bloque 5, Lote 3) (Michelle Kelson)
Resolution No. 335 - 2018 Release of Covenants - 28, 42 and 53 Hasbrouck Street Resolution authorizing the execution of Release of Restrictive Covenants and Right of Re-Entry from deeds issued to 28 Hasbrouck Realty Partners LLC, 42 Hasbrouck Realty Partners LLC, and 53 Hasbrouck Realty Partners LLC to the premises known as 28 Hasbrouck Street, 42 Hasbrouck Street, and 53 Hasbrouck Street, respectively. (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a 28 Hasbrouck Realty Partners LLC, 42 Hasbrouck Realty Partners LLC, y 53 Hasbrouck Realty Partners LLC a las instalaciones conocidas como la 28 de la Calle Hasbrouck, 42 de la Calle Hasbrouck y 53 de la Calle Hasbrouck, (Michelle Kelson)
Resolution No. 336 - 2018 Release of Covenants - 117 Johnston Street Resolution authorizing the execution of a release of restrictive covenants and right of re-entry from a deed issued to 120 Johnston Street, LLC to the premises known as 117 Johnston Street (Section 18, Block 11, Lot 14) (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a 120 Johnston Street, LLC para las instalaciones conocidas como la 117 de la Calle Johnston (Sección 18, Bloque 11, Lote 14) (Michelle Kelson)
Resolution No. 337 - 2018 Release of Covenants - 128 Dubois Street, 197 First Street, and 44 S. Miller Street Resolution authorizing the execution of Release of Restrictive Covenants and Right of Re-Entry from deeds issued to Old Newburgh Redevelopment Partnership, LP and Araceli Mendoza, respectively, to the premises known as 128 Dubois Street; deeds issued to IMC Mortgage Company and Deutsche Bank National Trust Company, as Trustee for J.P. Morgan Mortgage Association- Trust 2007-CH3, respectively, to the premises known as 197 First Street; and a deed to Claudia Williams to the premises known as 44 S. Miller Street. (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a “Old Newburgh Redevelopment Partnership, LP” y Araceli Mendoza, respectivamente, para las instalaciones conocidas como la 128 de la Calle Dubois; títulos emitidos a IMC Mortgage Company y Deutsche Bank National Trust Company, como administrador para la Asociación Hipotecaria J.P. Morgan – Fiduciaria 2007-CH3, respectivamente para las instalaciones conocidas como la 197 de la Calle First; y un título de propiedad para Claudia Williams para las instalaciones conocidas como la 44 de la Calle S. Miller. (Michelle Kelson)
Resolution No. 338 - 2018 Extension to rehabilitate 254 Liberty Street Resolution authorizing a nine month extension of time to rehabilitate the premises known as 254 Liberty Street (Section 18, Block 6, Lot 26) in the City of Newburgh. (Michelle Kelson) Una resolución autorizando una extensión de tiempo por nueve meses para rehabilitar las instalaciones conocidas como la 254 de la Calle Liberty (Sección 18, Bloque 6, Lote 26) en la Ciudad de Newburgh. (Michelle Kelson)
Resolution No. 339 - 2018 Amend 2018 Personnel Book to add a Temporary Sergeant in Police Department Resolution amending the 2018 personnel analysis book to add one Sergeant position on a temporary basis in the City of Newburgh Police Department. (Chief Douglas Solomon) Una resolución enmendando el libro de análisis del personal del 2018 para agregar una posición de Sargento en una base temporal en el Departamento de Policía de la Ciudad de Newburgh. (Jefe Douglas Solomon)
Resolution No. 340 - 2018 Clean Harbors Agreement for clean up of firefighting foam Resolution authorizing the City Manager to execute a stand-by emergency services agreement with Clean Harbors Environmental Services, Inc. to contain, collect and properly dispose of aqueous film forming foams. (Acting Chief Ahlers) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo de servicios de emergencia de reserva con “Clean Harbors Environmental Services, Inc.” Para contener, recolectar y disponer adecuadamente de espumas de formación acuosas. (Jefe Interino Ahlers)
Resolution No. 341 - 2018 Military Leave MOA with IAFF Local 589 Resolution approving a memorandum of agreement with the Local 589 International Association of Firefighters to provide certain additional benefits to members who have been called to active military duty. (Acting Chief Ahlers & Michelle Kelson) Una resolución aprobando un memorándum de acuerdo con la Asociación Internacional de Bomberos Local 589 para proporcionar ciertos beneficios adicionales a miembros que hayan sido llamados al servicio militar activo. (Jefe Interino Ahlers y Michelle Kelson)
Resolution No. 342 - 2018 Appointing Commissioners of Deeds Resolution to appoint Commissioners of Deeds for January 1, 2019 through December 31, 2020. (Michelle Kelson) Una resolución para nombrar comisionados de hechos por el término del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. (Michelle Kelson)
Ordinance No. 5 - 2018 Anti-Harassment Policy amendment -- Sexual Harassment Prevention Policy Ordinance amending Chapter 34, Article III of the Code of the City of Newburgh entitled “Equal Employment Opportunity and Anti-Harassment Policy” and adding new Article IV entitled “Sexual Harassment Prevention Policy” . (Michelle Kelson) Una ordenanza enmendando el Capítulo 34, Articulo III del Código de la Ciudad de Newburgh titulado “Póliza en Contra del Acoso y Oportunidad de Empleo Igualitaria” y agregando el nuevo Articulo IV titulado “Póliza de Prevención de Acoso Sexual” (Michelle Kelson)
Local Law No. 4 - 2018 to override the property tax cap for fiscal year 2019 Local law authorizing a property tax levy in excess of the limit established in General Municipal Law Section 3-c. (Michelle Kelson) Ley local que autoriza una tasa de impuesto sobre propiedades en exceso del límite establecido en la Ley Municipal General Sección 3-c. (Michelle Kelson)
Resolution No. 343 - 2018 Public Hearing -- Concerning a Local Law to increase sewer rent Resolution scheduling a public hearing for November 26, 2018 to hear public comment concerning a local law amending section 248-1(B)(1) entitled “Sewer Use Rents” to increase the sewer use rents to 108 percent of the customer's annual water bill. (Michelle Kelson) Una resolución programando una audiencia pública para el 26 de noviembre de 2018 para escuchar comentarios públicos con respecto a una ley local enmendando sección 248-1(B)(1) titulado “Alquiler del Uso de Alcantarillado” para incrementar el use de alquiler del uso del alcantarillado al 108 por ciento de la factura anual del agua del cliente. (Michelle Kelson)
Local Law No. 4 - 2018 to override the property tax cap for fiscal year 2019 Local law authorizing a property tax levy in excess of the limit established in General Municipal Law Section 3-c. (Michelle Kelson) Ley local que autoriza una tasa de impuesto sobre propiedades en exceso del límite establecido en la Ley Municipal General Sección 3-c. (Michelle Kelson)
Resolution No. 344 - 2018 Declaring Sonya Dixon Day A Resolution of the City Council of the City of Newburgh Declaring November 17, 2018 as Sonya Dixon Day in the City of Newburgh. (As per Councilman Grice) Una resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Newburgh declarando el 17 de noviembre de 2018 como el Día de Sonya Dixon en la Ciudad de Newburgh. (A pedido del Concejal Grice)
Resolution No. 345 - 2018 Authorizing a Payment of Claim A resolution authorizing the City Manager to execute a payment of claim with Allstate Insurance Company a/s/o Phillip Legnini in the amount of $2,865.11 Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad para ejecutar un pago de reclamo con Allstate Insurance Company a/s/o Pillip Legnini por la cantidad de $2,865.11
Resolution No. 346 - 2018 Amending Resolution 333-2017 Resolution amending resolution No.: 333- 2017, the 2018 budget for the City of Newburgh, New York to transfer $316,962.67 within the self insurance fund. Una resolución enmendando la Resolución No.: 333-2017, el presupuesto del 2018 para la Ciudad de Newburgh, Nueva York para transferir $316,962.67 dentro del fondo de auto seguranza.
Final Comments from the City Council
Final Comments from the City Council/ Comentarios Finales del Ayuntamiento: Adjournment/ Aplazamiento:
Mayor/Alcaldesa 1. Prayer/ Rezo 2. Pledge of Allegiance/Juramento a la Alianza City Clerk:/Secretaria de la Ciudad 3. Roll Call/ Lista de Asistencia
Communications/Communicaciones Approval of Minutes for the meeting of October 22, 2018 Aprobación de los minutos de la reunión del 22 de octubre de 2018
City Manager Update / Gerente de la Ciudad pone al día a la audiencia de los planes de cada departamento
Public Hearing -- 2019 Budget A public hearing will be held on Tuesday, November 13, 2018 to hear comment on the 2019 budget for the City of Newburgh. Una audiencia pública se llevara a cabo el martes, 13 de noviembre de 2018 para escuchar comentarios sobre el presupuesto del 2019 para la Ciudad de Newburgh.
Comments from the public regarding agenda and general matters of City Business/Comentarios del público con respecto a la agenda y sobre asuntos generales de la Ciudad.
Comments from the City Council
Comments from the Council regarding the agenda/Comentarios del Consejo con respecto a la agenda
City Manager’s Report/ Informe del Gerente de la Ciudad Resolution No. 321 - 2018 Proposal with O'Brien & Gere for Engineering Services at Brown's Pond Resolution authorizing the City Manager to accept a proposal and execute an professional engineering services agreement with O’Brien & Gere Engineers, Inc. for evaluation and rehabilitation investigation of the Brown's Pond spillway at a cost of $47,000.00. (Jason Morris) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a aceptar una propuesta y ejecutar un acuerdo de servicios de ingeniería profesional con “O’Brien & Gere Engineers, Inc.” para evaluación e investigación de rehabilitación del desagüe del Charco de Brown a un costo de $47,000.00 (Jason Morris)
Resolution No. 322 - 2018 Contract Agreement with Inframark, LLC to Operate the WWTP Resolution authorizing the City Manager to execute a Wastewater Treatment Plant Operation and Maintenance Agreement with Inframark, LLC for the operation, maintenance and management of the City Waste Water Treatment Plant. (Jason Morris) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo de mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales con “Inframark, LLC” para la administración, mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de la Ciudad. (Jason Morris)
Resolution No. 323 - 2018 Supplemental Agreement#1 with NYSDOT for the Lake Drive Bridge Replacement Resolution authorizing the City Manager to execute Supplemental Agreement No. 1 with the New York State Department of Transportation to fund in the first instance 100% of the federal-aid and non-federal aid eligible costs for the right-of-way acquisition work for the replacement of the Lake Drive Bridge. (Jason Morris) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar el Acuerdo Suplementario No. 1 con el Departamento de Transportación del Estado de Nueva York para financiar en la primera instancia 100% de los costos elegibles de la ayuda federal y ayuda no federal para la adquisición de trabajo del reemplazo del puente “Lake Drive”. (Jason Morris)
Resolution No. 324 - 2018 Orange County tax exemption agreement -- City of Newburgh water supply property Resolution requesting an exemption from County taxes for the City's reservoir and filter plant properties for the year 2020. (Charles Duffy & Michelle Kelson) Una resolución solicitando una exención de los impuestos del Condado para las propiedades de la planta de depósito y filtro para el año 2020. (Charles Duffy y Michelle Kelson)
Resolution No. 325 - 2018 Surplus bluestone Resolution declaring bluestone slate as surplus and authorizing disposition to the owner of property located at 55 Broad Street. (Michelle Kelson) Una resolución declarando el material “bluestone” como excedente y autorizando su disposición al dueño de la propiedad ubicada en la 55 de la Calle Broad. (Michelle Kelson)
Resolution No. 326 - 2018 Emergency Water Agreement with Town of New Windsor Resolution authorizing the City Manager to execute an inter-municipal emergency water supply agreement with the Town of New Windsor. (Wayne Vradenburgh, Jason Morris & Michelle Kelson) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo inter-municipal de abastecimiento de agua de emergencia con la Ciudad de New Windsor. (Wayne Vradenburgh, Jason Morris y Michelle Kelson)
Resolution No. 327 - 2018 To Accept FY2019 CDBG Funding Resolution adopting the City of Newburgh’s Consolidated Housing and Community Development Strategy and Action Plan for Fiscal Year 2019. (Ali Church) Una resolución adoptando el Plan de Acción y Estrategia de Desarrollo Comunitario y Vivienda Consolidada de la Ciudad de Newburgh para el Año Fiscal 2019. (Ali Church)
Resolution No. 328 - 2018 Purchase of 260 Liberty Street Resolution to authorize the conveyance or real property known as 260 Liberty Street (Section 18, Block 6, Lot 30) at private sale to Jeremy Moore and Heather Moore for the amount of $1,090.00. (Ali Church) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 260 de la Calle Liberty (Sección 18, Bloque 6, Lote 30) en una venta privada a Jeremy Moore y Heather Moore por la cantidad de $1,090.00. (Ali Church)
Resolution No. 329 - 2018 Purchase of 379 First Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 379 First Street (Section 28, Block 1, Lot 16) at private sale to Waldina Almazan for the amount of $65,000.00. (Ali Church) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 379 de la Calle First (Sección 28, Bloque 6, Lote 16) en una venta privada a Waldina Almazan por la cantidad de $65,000.00. (Ali Church)
Resolution No. 330 - 2018 Purchase of 10 Van Ness Street, 12 Van Ness Street and 34 Carter Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 10 Van Ness Street (Section 29, Block 5, Lot 25), 12 Van Ness Street (Section 29, Block 5, Lot 26) and 34 Carter Street (Section 22, Block 2, Lot 26) at private sale to Eulogio and Felderi Santiago for the total amount of $10,000.00. (Ali Church) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 10 de la Calle Van Ness (Sección 29, Bloque 5, Lote 25), 12 de la Calle Van Ness (Sección 29, Bloque 5, Lote 26) y la 34 de la Calle Carter (Sección 22, Bloque 2, Lote 26) en una venta privada a Eulogio y Felderi Santiago por la cantidad total de $10,000.00. (Ali Church)
Resolution 331 - 2018 Purchase of 60 Hasbrouck Street Resolution to authorize the conveyance of real property known as 60 Hasbrouck Street (Section 38, Block 3, Lot 56) at private sale to Michael Lavan for the amount of $50,000.00. (Ali Church) Una resolución para autorizar el traspaso de bienes raíces conocidas como la 60 de la Calle Hasbrouck (Sección 38, Bloque 5, Lote 56) en una venta privada a Michael Lavan por la cantidad de $50,000.00. (Ali Church)
Resolution No. 332 - 2018 Satisfaction of two Mortgages for 173 First Street Resolution authorizing the City Manager to execute satisfactions in connection with mortgages issued to 173 First Street Associates, L.P. for premises located at 173 First Street (Section 30, Block 2, Lot 6) (Ali Church) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad para ejecutar satisfacciones en conexión con las hipotecas emitidas a 173 First Street Associates, L.P. para las instalaciones ubicadas en la 173 de la Calle First (Sección 30, Bloque 2, Lote 6) (Ali Church)
Resolution No. 333 - 2018 Release of Covenants - 92 Fullerton Avenue Resolution authorizing the execution of a release of restrictive covenants and right of re-entry from a deed issued to Leonor Machuca to the premises known as 92 Fullerton Avenue (Section 21, Block 1, Lot 36) (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a Leonor Machuca a las instalaciones conocidas como la 92 de la Avenida Fullerton (Sección 21, Bloque 1, Lote 36) (Michelle Kelson)
Resolution No. 334 - 2018 Release of Covenants -- 167 Ann Street Resolution authorizing the execution of a release of restrictive covenants and right of re-entry from a deed issued to Calixto Cassas to the premises known as 167 Ann Street (Section 36, Block 5, Lot 3) (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a Calixto Cassas a las instalaciones conocidas como la 167 de la Calle Ann (Sección 36, Bloque 5, Lote 3) (Michelle Kelson)
Resolution No. 335 - 2018 Release of Covenants - 28, 42 and 53 Hasbrouck Street Resolution authorizing the execution of Release of Restrictive Covenants and Right of Re-Entry from deeds issued to 28 Hasbrouck Realty Partners LLC, 42 Hasbrouck Realty Partners LLC, and 53 Hasbrouck Realty Partners LLC to the premises known as 28 Hasbrouck Street, 42 Hasbrouck Street, and 53 Hasbrouck Street, respectively. (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a 28 Hasbrouck Realty Partners LLC, 42 Hasbrouck Realty Partners LLC, y 53 Hasbrouck Realty Partners LLC a las instalaciones conocidas como la 28 de la Calle Hasbrouck, 42 de la Calle Hasbrouck y 53 de la Calle Hasbrouck, (Michelle Kelson)
Resolution No. 336 - 2018 Release of Covenants - 117 Johnston Street Resolution authorizing the execution of a release of restrictive covenants and right of re-entry from a deed issued to 120 Johnston Street, LLC to the premises known as 117 Johnston Street (Section 18, Block 11, Lot 14) (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a 120 Johnston Street, LLC para las instalaciones conocidas como la 117 de la Calle Johnston (Sección 18, Bloque 11, Lote 14) (Michelle Kelson)
Resolution No. 337 - 2018 Release of Covenants - 128 Dubois Street, 197 First Street, and 44 S. Miller Street Resolution authorizing the execution of Release of Restrictive Covenants and Right of Re-Entry from deeds issued to Old Newburgh Redevelopment Partnership, LP and Araceli Mendoza, respectively, to the premises known as 128 Dubois Street; deeds issued to IMC Mortgage Company and Deutsche Bank National Trust Company, as Trustee for J.P. Morgan Mortgage Association- Trust 2007-CH3, respectively, to the premises known as 197 First Street; and a deed to Claudia Williams to the premises known as 44 S. Miller Street. (Michelle Kelson) Una resolución autorizando la ejecución de la liberación de cláusulas restrictivas y derecho de reingreso de un título emitido a “Old Newburgh Redevelopment Partnership, LP” y Araceli Mendoza, respectivamente, para las instalaciones conocidas como la 128 de la Calle Dubois; títulos emitidos a IMC Mortgage Company y Deutsche Bank National Trust Company, como administrador para la Asociación Hipotecaria J.P. Morgan – Fiduciaria 2007-CH3, respectivamente para las instalaciones conocidas como la 197 de la Calle First; y un título de propiedad para Claudia Williams para las instalaciones conocidas como la 44 de la Calle S. Miller. (Michelle Kelson)
Resolution No. 338 - 2018 Extension to rehabilitate 254 Liberty Street Resolution authorizing a nine month extension of time to rehabilitate the premises known as 254 Liberty Street (Section 18, Block 6, Lot 26) in the City of Newburgh. (Michelle Kelson) Una resolución autorizando una extensión de tiempo por nueve meses para rehabilitar las instalaciones conocidas como la 254 de la Calle Liberty (Sección 18, Bloque 6, Lote 26) en la Ciudad de Newburgh. (Michelle Kelson)
Resolution No. 339 - 2018 Amend 2018 Personnel Book to add a Temporary Sergeant in Police Department Resolution amending the 2018 personnel analysis book to add one Sergeant position on a temporary basis in the City of Newburgh Police Department. (Chief Douglas Solomon) Una resolución enmendando el libro de análisis del personal del 2018 para agregar una posición de Sargento en una base temporal en el Departamento de Policía de la Ciudad de Newburgh. (Jefe Douglas Solomon)
Resolution No. 340 - 2018 Clean Harbors Agreement for clean up of firefighting foam Resolution authorizing the City Manager to execute a stand-by emergency services agreement with Clean Harbors Environmental Services, Inc. to contain, collect and properly dispose of aqueous film forming foams. (Acting Chief Ahlers) Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad a ejecutar un acuerdo de servicios de emergencia de reserva con “Clean Harbors Environmental Services, Inc.” Para contener, recolectar y disponer adecuadamente de espumas de formación acuosas. (Jefe Interino Ahlers)
Resolution No. 341 - 2018 Military Leave MOA with IAFF Local 589 Resolution approving a memorandum of agreement with the Local 589 International Association of Firefighters to provide certain additional benefits to members who have been called to active military duty. (Acting Chief Ahlers & Michelle Kelson) Una resolución aprobando un memorándum de acuerdo con la Asociación Internacional de Bomberos Local 589 para proporcionar ciertos beneficios adicionales a miembros que hayan sido llamados al servicio militar activo. (Jefe Interino Ahlers y Michelle Kelson)
Resolution No. 342 - 2018 Appointing Commissioners of Deeds Resolution to appoint Commissioners of Deeds for January 1, 2019 through December 31, 2020. (Michelle Kelson) Una resolución para nombrar comisionados de hechos por el término del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. (Michelle Kelson)
Ordinance No. 5 - 2018 Anti-Harassment Policy amendment -- Sexual Harassment Prevention Policy Ordinance amending Chapter 34, Article III of the Code of the City of Newburgh entitled “Equal Employment Opportunity and Anti-Harassment Policy” and adding new Article IV entitled “Sexual Harassment Prevention Policy” . (Michelle Kelson) Una ordenanza enmendando el Capítulo 34, Articulo III del Código de la Ciudad de Newburgh titulado “Póliza en Contra del Acoso y Oportunidad de Empleo Igualitaria” y agregando el nuevo Articulo IV titulado “Póliza de Prevención de Acoso Sexual” (Michelle Kelson)
Local Law No. 4 - 2018 to override the property tax cap for fiscal year 2019 Local law authorizing a property tax levy in excess of the limit established in General Municipal Law Section 3-c. (Michelle Kelson) Ley local que autoriza una tasa de impuesto sobre propiedades en exceso del límite establecido en la Ley Municipal General Sección 3-c. (Michelle Kelson)
Resolution No. 343 - 2018 Public Hearing -- Concerning a Local Law to increase sewer rent Resolution scheduling a public hearing for November 26, 2018 to hear public comment concerning a local law amending section 248-1(B)(1) entitled “Sewer Use Rents” to increase the sewer use rents to 108 percent of the customer's annual water bill. (Michelle Kelson) Una resolución programando una audiencia pública para el 26 de noviembre de 2018 para escuchar comentarios públicos con respecto a una ley local enmendando sección 248-1(B)(1) titulado “Alquiler del Uso de Alcantarillado” para incrementar el use de alquiler del uso del alcantarillado al 108 por ciento de la factura anual del agua del cliente. (Michelle Kelson)
Local Law No. 4 - 2018 to override the property tax cap for fiscal year 2019 Local law authorizing a property tax levy in excess of the limit established in General Municipal Law Section 3-c. (Michelle Kelson) Ley local que autoriza una tasa de impuesto sobre propiedades en exceso del límite establecido en la Ley Municipal General Sección 3-c. (Michelle Kelson)
Resolution No. 344 - 2018 Declaring Sonya Dixon Day A Resolution of the City Council of the City of Newburgh Declaring November 17, 2018 as Sonya Dixon Day in the City of Newburgh. (As per Councilman Grice) Una resolución del Concejo Municipal de la Ciudad de Newburgh declarando el 17 de noviembre de 2018 como el Día de Sonya Dixon en la Ciudad de Newburgh. (A pedido del Concejal Grice)
Resolution No. 345 - 2018 Authorizing a Payment of Claim A resolution authorizing the City Manager to execute a payment of claim with Allstate Insurance Company a/s/o Phillip Legnini in the amount of $2,865.11 Una resolución autorizando al Gerente de la Ciudad para ejecutar un pago de reclamo con Allstate Insurance Company a/s/o Pillip Legnini por la cantidad de $2,865.11
Resolution No. 346 - 2018 Amending Resolution 333-2017 Resolution amending resolution No.: 333- 2017, the 2018 budget for the City of Newburgh, New York to transfer $316,962.67 within the self insurance fund. Una resolución enmendando la Resolución No.: 333-2017, el presupuesto del 2018 para la Ciudad de Newburgh, Nueva York para transferir $316,962.67 dentro del fondo de auto seguranza.
Final Comments from the City Council
Final Comments from the City Council/ Comentarios Finales del Ayuntamiento: Adjournment/ Aplazamiento: